-
COMPLETE ENERGY CONTROLS LTD. - 2 Melville Street, Falkirk, Stirlingshire, FK1 1HZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC547712
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Melville Street
- Falkirk
- Stirlingshire
- FK1 1HZ
- Scotland 2 Melville Street, Falkirk, Stirlingshire, FK1 1HZ, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- CLIFFORD, John Joseph
- RUDDER, Jennifer Lynn
- WOOD, Simon James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.10.2016
- Alter der Firma 2016-10-13 7 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Russell David Stuart
- -
- Learnd Limited
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-26
- Letzte Einreichung: 2022-10-12
-
COMPLETE ENERGY CONTROLS LTD. Firmenbeschreibung
- COMPLETE ENERGY CONTROLS LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC547712. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.10.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2 Melville Street erreicht werden.
Jetzt sichern COMPLETE ENERGY CONTROLS LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Complete Energy Controls Ltd. - 2 Melville Street, Falkirk, Stirlingshire, FK1 1HZ, Grossbritannien
- 2016-10-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COMPLETE ENERGY CONTROLS LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
capital-name-of-class-of-shares (2023-05-09) - SH08
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-05-03) - PSC02
-
memorandum-articles (2023-05-03) - MA
-
resolution (2023-05-03) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-03-06) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-02-27) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-05-03) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2023-05-10) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-05-16) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-05-03) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-05-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
capital-allotment-shares (2022-08-30) - SH01
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2022-08-25) - RP04CS01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2022-08-16) - RP04SH01
-
capital-allotment-shares (2022-08-16) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-10-18) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-06-03) - SH01
-
resolution (2021-05-27) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-05-27) - MA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-02-24) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-22) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-15) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-09-22) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-allotment-shares (2019-06-05) - SH01
-
resolution (2019-06-05) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-06-05) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2019-06-05) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-06-04) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-05) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-04) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-07) - CH01
-
incorporation-company (2016-10-13) - NEWINC