-
WESTMINSTER FUELS AND LUBRICANTS LIMITED - 25, Bothwell Street, Glasgow, G2 6NL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC501952
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 25
- Bothwell Street
- Glasgow
- G2 6NL 25, Bothwell Street, Glasgow, G2 6NL UK
Management
- Geschäftsführung
- COX, Teresa Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.03.2015
- Gelöscht am:
- 2020-08-19
- SIC/NACE
- 46120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Ms Teresa Mary Cox
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- WESTMINSTER PETROLEUM LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-04-13
- Letzte Einreichung: 2019-03-30
-
WESTMINSTER FUELS AND LUBRICANTS LIMITED Firmenbeschreibung
- WESTMINSTER FUELS AND LUBRICANTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC501952. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 30.03.2015 registriert. WESTMINSTER FUELS AND LUBRICANTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WESTMINSTER PETROLEUM LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46120" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 25 erreicht werden.
Jetzt sichern WESTMINSTER FUELS AND LUBRICANTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Westminster Fuels And Lubricants Limited - 25, Bothwell Street, Glasgow, G2 6NL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WESTMINSTER FUELS AND LUBRICANTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-08-19) - GAZ2
-
liquidation-compulsory-notice-winding-up-order-court-scotland (2020-02-18) - WU01(Scot)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-18) - AD01
-
liquidation-compulsory-return-final-meeting-court-scotland (2020-05-19) - WU15(Scot)
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-10) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-10) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-10) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-10) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-29) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-28) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-11-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-08) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-19) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-19) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-04-19) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-06) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-22) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-12-31) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-22) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-26) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-08-20) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-30) - CH01
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-07) - CERTNM
-
resolution (2015-05-07) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2015-03-30) - NEWINC
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-22) - CH01