-
ALLT CHOILLE-RAIS HYDRO LTD - 1st Floor Cef Building Inveralmond Road, Inveralmond Industrial Estate, Perth, PH1 3TW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC493178
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st Floor Cef Building Inveralmond Road
- Inveralmond Industrial Estate
- Perth
- PH1 3TW
- Scotland 1st Floor Cef Building Inveralmond Road, Inveralmond Industrial Estate, Perth, PH1 3TW, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- BURGESS, Benjamin Michael
- SHERMAN, Jemma Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2014
- Alter der Firma 2014-12-11 9 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ghh Newco Ltd
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- NEVIS RANGE HYDRO COMPANY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-25
- Letzte Einreichung: 2023-12-11
-
ALLT CHOILLE-RAIS HYDRO LTD Firmenbeschreibung
- ALLT CHOILLE-RAIS HYDRO LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC493178. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.12.2014 registriert. ALLT CHOILLE-RAIS HYDRO LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NEVIS RANGE HYDRO COMPANY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1St Floor Cef Building Inveralmond Road erreicht werden.
Jetzt sichern ALLT CHOILLE-RAIS HYDRO LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Allt Choille-Rais Hydro Ltd - 1st Floor Cef Building Inveralmond Road, Inveralmond Industrial Estate, Perth, PH1 3TW, Grossbritannien
- 2014-12-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ALLT CHOILLE-RAIS HYDRO LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-person-director-company-with-change-date (2024-02-26) - CH01
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-10-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-02-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-10-10) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-05-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-05-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-12-13) - CS01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2021-11-01) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2021-11-01) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-01) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-08-04) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-10) - MR04
-
resolution (2020-01-13) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-03-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-05-11) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-12-24) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-24) - CS01
-
resolution (2019-12-18) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-13) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-12) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-12) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-03-25) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-12) - PSC02
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-14) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-11) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-24) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-02-21) - AA01
-
capital-allotment-shares (2016-03-02) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-14) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-05-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-22) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-12-22) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-05) - AA01
-
capital-allotment-shares (2015-10-13) - SH01
-
resolution (2015-10-02) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-29) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-20) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-12-11) - NEWINC