-
DEMPSTER AND TAYLOR LTD - 8 Jamaica Street, Greenock, PA15 1XU, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC489072
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 Jamaica Street
- Greenock
- PA15 1XU
- Scotland 8 Jamaica Street, Greenock, PA15 1XU, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- MR ALLAN DAVID MCGHEE
- MRS LINDA MCLEAN THOMAS
- COLLINS, Michael
- QUINN, Stephanie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.10.2014
- Alter der Firma 2014-10-16 9 Jahre
- SIC/NACE
- 96030
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-03-31
- Letzte Einreichung: 2023-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-11
- Letzte Einreichung: 2023-03-28
-
DEMPSTER AND TAYLOR LTD Firmenbeschreibung
- DEMPSTER AND TAYLOR LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC489072. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.10.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96030" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 8 Jamaica Street erreicht werden.
Jetzt sichern DEMPSTER AND TAYLOR LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dempster And Taylor Ltd - 8 Jamaica Street, Greenock, PA15 1XU, Scotland, Grossbritannien
- 2014-10-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DEMPSTER AND TAYLOR LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-04-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-03-28) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-04-11) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-04-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-04-11) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-04-11) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-04-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-24) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-03-28) - PSC04
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-18) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-21) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-21) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-12-21) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-21) - PSC07
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-11-23) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-10-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-01) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-01) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-22) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-07-06) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-07-06) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-26) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-10-26) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-10-16) - NEWINC