-
BLAZING KEEP LIMITED - The Old School House, 101 Portman Street, Glasgow, G41 1EJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC479036
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old School House
- 101 Portman Street
- Glasgow
- G41 1EJ
- Scotland The Old School House, 101 Portman Street, Glasgow, G41 1EJ, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- ALAE-CAREW, Naysun Darren
- MARRIOTT, Henry John
- VAN DER WATT, Francois Peter Andre
- WALKER, Steven John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.06.2014
- Alter der Firma 2014-06-03 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62011
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Henry John Marriott
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-17
- Letzte Einreichung: 2020-06-03
-
BLAZING KEEP LIMITED Firmenbeschreibung
- BLAZING KEEP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC479036. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.06.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62011" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Old School House erreicht werden.
Jetzt sichern BLAZING KEEP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Blazing Keep Limited - The Old School House, 101 Portman Street, Glasgow, G41 1EJ, Grossbritannien
- 2014-06-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BLAZING KEEP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
resolution (2020-11-16) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-03-31) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-07) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-08-31) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-22) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-04) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-04-12) - SH01
-
resolution (2019-04-12) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-08) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-04-17) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-04-17) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-04-20) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-15) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-15) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-15) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-10) - CH01
-
resolution (2017-10-27) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-28) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-07-10) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-10) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-07-10) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-14) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-10) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-29) - AA
-
second-filing-capital-allotment-shares (2016-12-28) - RP04SH01
-
resolution (2016-12-28) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-23) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-11-22) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-22) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-04) - AP01
-
resolution (2015-02-05) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-02-05) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-27) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-23) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-09-25) - AP03
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-11-20) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-11-06) - SH01
-
resolution (2014-11-06) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-11-06) - SH02
-
capital-allotment-shares (2014-09-17) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-09-17) - SH02
-
resolution (2014-09-17) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2014-06-03) - NEWINC