-
BRAVEHEART INDUSTRIES - James Miller House, 98w, West George Street, Glasgow, G2 1QR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC477402
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- James Miller House
- 98w, West George Street
- Glasgow
- G2 1QR
- Scotland James Miller House, 98w, West George Street, Glasgow, G2 1QR, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- JACKSON, Tom
- MCGLYNN, Paula Elizabeth
- BINNIE, Vikki Amanda
- FRANKLIN, Thankachan
- LAING, Dughall Macruaraidh
- WEAVER, Beth, Professor
- MATHEWS, Enoch
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc-limited-exemption
- Gründungsdatum
- 12.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Mr Thomas Allen Jackson
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-09
- Letzte Einreichung: 2021-08-26
-
BRAVEHEART INDUSTRIES Firmenbeschreibung
- BRAVEHEART INDUSTRIES ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc-limited-exemption registrierte Firma mit der Register-Nr. SC477402. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 7 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über James Miller House erreicht werden.
Jetzt sichern BRAVEHEART INDUSTRIES HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Braveheart Industries - James Miller House, 98w, West George Street, Glasgow, G2 1QR, Grossbritannien
- 2014-05-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRAVEHEART INDUSTRIES aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-06-10) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-30) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-10) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-04-20) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-08-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-11) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-22) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-22) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-22) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-21) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-21) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-19) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-08-03) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-10) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-18) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-10) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-18) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-07) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2019-02-26) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-18) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-03-09) - DISS40
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-01) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-01) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-11-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2016-06-03) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-12-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-12-23) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-07-20) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2015-05-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2014-09-04) - AD03
-
incorporation-company (2014-05-12) - NEWINC
-
change-sail-address-company-with-new-address (2014-08-30) - AD02