-
LEVEN CARS GROUP LIMITED - C/O Leonard Curtis Recovery Ltd 4th Floor, 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC468400
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Leonard Curtis Recovery Ltd 4th Floor
- 58 Waterloo Street
- Glasgow
- G2 7DA C/O Leonard Curtis Recovery Ltd 4th Floor, 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA UK
Management
- Geschäftsführung
- MCMAHON, Christopher Michael
- MCMAHON, Hugh Patrick
- Prokuristen
- GREEN, Emma Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.01.2014
- Alter der Firma 2014-01-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 45111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Hugh Patrick Mcmahon
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-12-19
- Letzte Einreichung: 2018-12-05
-
LEVEN CARS GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- LEVEN CARS GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC468400. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.01.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über C/o Leonard Curtis Recovery Ltd 4Th Floor erreicht werden.
Jetzt sichern LEVEN CARS GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Leven Cars Group Limited - C/O Leonard Curtis Recovery Ltd 4th Floor, 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA, Grossbritannien
- 2014-01-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LEVEN CARS GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-in-administration-progress-report-scotland (2021-08-16) - AM10(Scot)
-
liquidation-in-administration-progress-report-scotland (2021-11-30) - AM10(Scot)
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation-scotland-2 (2021-12-08) - AM22(Scot)
-
liquidation-in-administration-removal-of-administrator-from-office-scotland (2021-07-13) - AM16(Scot)
-
liquidation-in-administration-appointment-of-a-replacement-or-additional-administrator-scotland (2021-07-13) - AM11(Scot)
-
liquidation-in-administration-progress-report-scotland (2021-02-10) - AM10(Scot)
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-in-administration-notice-administrators-proposals-scotland (2020-03-02) - AM03(Scot)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-13) - AD01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator-scotland (2020-01-13) - AM01(Scot)
-
liquidation-in-administration-extension-of-period-scotland (2020-12-24) - AM19(Scot)
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached-scotland (2020-05-27) - AM02(Scot)
-
liquidation-in-administration-progress-report-scotland (2020-08-13) - AM10(Scot)
-
liquidation-in-administration-notice-deemed-approval-of-proposals-scotland (2020-03-23) - AM06(Scot)
-
liquidation-in-administration-extension-of-period-scotland (2020-10-08) - AM19(Scot)
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-07-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-02-08) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-23) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-03) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-22) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-22) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-07-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2016-10-20) - RP04AR01
-
annual-return-company (2016-02-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-medium (2016-09-14) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-10-20) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-28) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-09) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-medium (2015-10-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-01) - AD01
-
incorporation-company (2014-01-27) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-08) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-05-08) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-05-08) - AP03