-
J W SUTHERLAND PROPERTY DEVELOPMENTS & GENERAL BUILDERS LIMITED - West Point, Keiss, Wick, KW1 4XF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC466846
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- West Point
- Keiss
- Wick
- KW1 4XF
- Scotland West Point, Keiss, Wick, KW1 4XF, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- SUTHERLAND, Paul Michael
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.01.2014
- Gelöscht am:
- 2023-02-07
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Michael Sutherland
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-17
-
J W SUTHERLAND PROPERTY DEVELOPMENTS & GENERAL BUILDERS LIMITED Firmenbeschreibung
- J W SUTHERLAND PROPERTY DEVELOPMENTS & GENERAL BUILDERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC466846. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 08.01.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über West Point erreicht werden.
Jetzt sichern J W SUTHERLAND PROPERTY DEVELOPMENTS & GENERAL BUILDERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: J W Sutherland Property Developments & General Builders Limited - West Point, Keiss, Wick, KW1 4XF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu J W SUTHERLAND PROPERTY DEVELOPMENTS & GENERAL BUILDERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-voluntary (2023-02-07) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2022
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2022-01-06) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-01-07) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-17) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2022-11-16) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2022-11-22) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-17) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-17) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-08-21) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-04) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-10-04) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-19) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-13) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-02) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-02-06) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-04) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-03) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2015-12-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-01-08) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-26) - AD01