-
SPRING DISTRIBUTION (SCOTLAND) LIMITED - 34 Inchmuir Road, Whitehill Industrial Estate, Bathgate, West Lothian, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC466064
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 34 Inchmuir Road
- Whitehill Industrial Estate
- Bathgate
- West Lothian
- EH48 2EP 34 Inchmuir Road, Whitehill Industrial Estate, Bathgate, West Lothian, EH48 2EP UK
Management
- Geschäftsführung
- CHRISTIAN, Scott
- GARVEY, Ronnie Tony
- WARD, John James
- WARD, Lesley Sarah
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.12.2013
- Alter der Firma 2013-12-18 10 Jahre
- SIC/NACE
- 52103
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Mr Ronnie Tony Garvie
- -
- R & R C Bond (Holdings) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- FORTY EIGHT SHELF (266) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-31
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-01
- Letzte Einreichung: 2023-12-18
-
SPRING DISTRIBUTION (SCOTLAND) LIMITED Firmenbeschreibung
- SPRING DISTRIBUTION (SCOTLAND) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC466064. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.12.2013 registriert. SPRING DISTRIBUTION (SCOTLAND) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FORTY EIGHT SHELF (266) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52103" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 34 Inchmuir Road erreicht werden.
Jetzt sichern SPRING DISTRIBUTION (SCOTLAND) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Spring Distribution (Scotland) Limited - 34 Inchmuir Road, Whitehill Industrial Estate, Bathgate, West Lothian, Grossbritannien
- 2013-12-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SPRING DISTRIBUTION (SCOTLAND) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
resolution (2024-02-08) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-02-08) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-02-08) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-02-08) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-01-30) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-02-08) - AP01
-
memorandum-articles (2024-02-08) - MA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-11-23) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-03) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-10-10) - AA
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-02) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-18) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-06) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-01) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-01-31) - CERTNM
-
resolution (2014-01-31) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-12-18) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-12-18) - NEWINC