-
HICKORY (SCOTLAND) LIMITED - Stuart House Eskmills Park, Station Road, Musselburgh, Midlothian, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC430051
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Stuart House Eskmills Park
- Station Road
- Musselburgh
- Midlothian
- EH21 7PQ Stuart House Eskmills Park, Station Road, Musselburgh, Midlothian, EH21 7PQ UK
Management
- Geschäftsführung
- GALBRAITH, Brian
- IRELAND, Susan Priscilla
- STUBBS, Stephanie Angela
- HARRISON, Libby
- Prokuristen
- BROUSSINE, Ivan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.08.2012
- Alter der Firma 2012-08-09 11 Jahre
- SIC/NACE
- 56210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Brian Galbraith
- Mrs Susan Priscilla Ireland
- Ms Susan Priscilla Ireland
- Mr Brian Galbraith
- Mrs Stephanie Angela Stubbs
- Ms Stephanie Angela Stubbs
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- GH EVENT CATERING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-08-23
- Letzte Einreichung: 2022-08-09
-
HICKORY (SCOTLAND) LIMITED Firmenbeschreibung
- HICKORY (SCOTLAND) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC430051. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.08.2012 registriert. HICKORY (SCOTLAND) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GH EVENT CATERING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56210" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Stuart House Eskmills Park erreicht werden.
Jetzt sichern HICKORY (SCOTLAND) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hickory (Scotland) Limited - Stuart House Eskmills Park, Station Road, Musselburgh, Midlothian, Grossbritannien
- 2012-08-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HICKORY (SCOTLAND) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-04-06) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-07-24) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-05) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-04-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-02) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-02) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-08-23) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-12) - CS01
-
certificate-change-of-name-company (2020-10-14) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-11-26) - SH01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2018-11-12) - RP04SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-22) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-05) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-21) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-13) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-09-07) - AP03
-
capital-allotment-shares (2016-09-07) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-11) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-14) - TM01
-
resolution (2015-05-07) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-07) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-02) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-05) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-04-29) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-03) - AD01
-
capital-allotment-shares (2012-10-18) - SH01
-
incorporation-company (2012-08-09) - NEWINC