-
INTELLIGENT PORTFOLIOS LIMITED - Gresham Chambers 3rd Floor, 45 West Nile Street, Glasgow, G1 2PT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC425342
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Gresham Chambers 3rd Floor
- 45 West Nile Street
- Glasgow
- G1 2PT
- Scotland Gresham Chambers 3rd Floor, 45 West Nile Street, Glasgow, G1 2PT, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- BREMNER, Thomas David
- MANSON, Alan Graeme
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.05.2012
- Gelöscht am:
- 2023-12-19
- SIC/NACE
- 66190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Intelligent Capital Group Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- INTELLIGENT CAPITAL (GLASGOW) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-10-31
- Letzte Einreichung: 2023-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-06-14
- Letzte Einreichung: 2021-05-31
-
INTELLIGENT PORTFOLIOS LIMITED Firmenbeschreibung
- INTELLIGENT PORTFOLIOS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC425342. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 31.05.2012 registriert. INTELLIGENT PORTFOLIOS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen INTELLIGENT CAPITAL (GLASGOW) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66190" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.05.2013.Die Firma kann schriftlich über Gresham Chambers 3Rd Floor erreicht werden.
Jetzt sichern INTELLIGENT PORTFOLIOS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Intelligent Portfolios Limited - Gresham Chambers 3rd Floor, 45 West Nile Street, Glasgow, G1 2PT, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu INTELLIGENT PORTFOLIOS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-09-20) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-09-25) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2023-10-03) - GAZ1(A)
-
gazette-dissolved-voluntary (2023-12-19) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-08-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-09) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-13) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-16) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-03) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-10) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-16) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-16) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-25) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-17) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-25) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-21) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-18) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-15) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-30) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-31) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-31) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-06-13) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2012-11-13) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-10-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-23) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-23) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-10-23) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-10-23) - AA01
-
incorporation-company (2012-05-31) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name (2012-06-13) - TM02