-
SYNETIQ GREENPARTS DATA SYSTEMS LIMITED - C/O Synetiq Ltd Balmore Road, Kirkintilloch, Glasgow, G64 4AB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC423321
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Synetiq Ltd Balmore Road
- Kirkintilloch
- Glasgow
- G64 4AB
- Scotland C/O Synetiq Ltd Balmore Road, Kirkintilloch, Glasgow, G64 4AB, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- COMBELLACK, Darren James
- IRVINE, Hamish Edward Thomson
- MARTIN, Richard
- PREBBLE, Allen William Frederick
- Prokuristen
- LESLIE, Hugh Alexander
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.05.2012
- Gelöscht am:
- 2023-06-20
- SIC/NACE
- 62012
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Ehemalige Namen
- GREEN PARTS DATA SYSTEMS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-05-03
-
SYNETIQ GREENPARTS DATA SYSTEMS LIMITED Firmenbeschreibung
- SYNETIQ GREENPARTS DATA SYSTEMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC423321. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 03.05.2012 registriert. SYNETIQ GREENPARTS DATA SYSTEMS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GREEN PARTS DATA SYSTEMS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.05.2013.Die Firma kann schriftlich über C/o Synetiq Ltd Balmore Road erreicht werden.
Jetzt sichern SYNETIQ GREENPARTS DATA SYSTEMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Synetiq Greenparts Data Systems Limited - C/O Synetiq Ltd Balmore Road, Kirkintilloch, Glasgow, G64 4AB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SYNETIQ GREENPARTS DATA SYSTEMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-voluntary (2023-06-20) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-03-29) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2023-04-04) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-02-10) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-07-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-02) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-18) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2021-11-30) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-04) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-15) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-31) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-24) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-02-08) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-17) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-01) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-16) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-07) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-06-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-10-16) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-09-07) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-09-07) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-09-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-09-07) - TM01
-
incorporation-company (2012-05-03) - NEWINC