-
CHRISTOPHER F. STAFFORD HOLDINGS LIMITED - Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, AB15 4YL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC416311
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Pinsent Masons Llp
- 13 Queens Road
- Aberdeen
- AB15 4YL Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, AB15 4YL UK
Management
- Geschäftsführung
- PUEYO ROBERTS, Gabriela
- WRIGHT, Jake Stephen Hockley
- Prokuristen
- BUPA SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.02.2012
- Gelöscht am:
- 2020-09-29
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Xeon Smiles Uk Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-06
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-15
- Letzte Einreichung: 2020-01-04
-
CHRISTOPHER F. STAFFORD HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- CHRISTOPHER F. STAFFORD HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC416311. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 06.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Pinsent Masons Llp erreicht werden.
Jetzt sichern CHRISTOPHER F. STAFFORD HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Christopher F. Stafford Holdings Limited - Pinsent Masons Llp, 13 Queens Road, Aberdeen, AB15 4YL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHRISTOPHER F. STAFFORD HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-07-14) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-04) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-07-06) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2019-06-26) - AA
-
legacy (2019-06-26) - PARENT_ACC
-
legacy (2019-06-26) - AGREEMENT2
-
legacy (2019-06-26) - GUARANTEE2
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-01) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-01) - AP01
-
legacy (2018-06-07) - GUARANTEE2
-
legacy (2018-06-07) - AGREEMENT2
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-21) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-14) - TM01
-
legacy (2018-06-07) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2018-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2017-07-13) - AP04
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2017-12-08) - CH04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-24) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-14) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-07-13) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-12) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-09) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-09) - TM01
-
resolution (2017-05-09) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-10) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-31) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-16) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-25) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-31) - AP01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2017-06-01) - RP04AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-03) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-07) - PSC07
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-07-09) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-02-21) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-02-21) - TM02
-
incorporation-company (2012-02-06) - NEWINC