-
THOMAS HANCOCK & COMPANY LIMITED - Finlay House, 10-14 West Nile Street, Glasgow, G1 2PP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC415173
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Finlay House
- 10-14 West Nile Street
- Glasgow
- G1 2PP Finlay House, 10-14 West Nile Street, Glasgow, G1 2PP UK
Management
- Geschäftsführung
- BLAKEY, Graham
- DUNKO, Daniel
- Prokuristen
- WILLIS, Timothy John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.01.2012
- Gelöscht am:
- 2019-12-02
- SIC/NACE
- 14132
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-10-23
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-23
-
THOMAS HANCOCK & COMPANY LIMITED Firmenbeschreibung
- THOMAS HANCOCK & COMPANY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC415173. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.01.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "14132" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Finlay House erreicht werden.
Jetzt sichern THOMAS HANCOCK & COMPANY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Thomas Hancock & Company Limited - Finlay House, 10-14 West Nile Street, Glasgow, G1 2PP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THOMAS HANCOCK & COMPANY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2019
-
gazette-dissolved-liquidation (2019-12-02) - GAZ2
-
liquidation-compulsory-early-dissolution-court-scotland (2019-09-02) - WU16(Scot)
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-compulsory-winding-up-order-scotland (2018-05-15) - 4.2(Scot)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-02) - AD01
-
liquidation-compulsory-appointment-provisional-liquidator-scotland (2018-05-02) - 4.9(Scot)
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-11) - CS01
-
liquidation-compulsory-notice-winding-up-scotland (2018-05-15) - CO4.2(Scot)
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-14) - AA
-
second-filing-capital-allotment-shares (2017-01-25) - RP04SH01
-
capital-allotment-shares (2017-01-30) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-01) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-07-12) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-26) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-12-04) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-04-22) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-01-26) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-26) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-01-26) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2013-02-12) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-06-10) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-02-20) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-22) - AA
-
capital-allotment-shares (2013-11-04) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-22) - AP01
-
capital-allotment-shares (2012-05-14) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-30) - AD01
-
incorporation-company (2012-01-23) - NEWINC