-
MYRETON WINDPOWER LTD - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC410291
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 272 Bath Street
- Glasgow
- G2 4JR
- Scotland 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- DEVON-LOWE, Karl Phillip
- MORGAN, William Laugharne
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-31 12 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-03-31
- Letzte Einreichung: 2020-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-14
- Letzte Einreichung: 2020-10-31
-
MYRETON WINDPOWER LTD Firmenbeschreibung
- MYRETON WINDPOWER LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC410291. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 272 Bath Street erreicht werden.
Jetzt sichern MYRETON WINDPOWER LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Myreton Windpower Ltd - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland, Grossbritannien
- 2011-10-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MYRETON WINDPOWER LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-18) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-05) - AP01
-
resolution (2018-06-11) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-19) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-19) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-26) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-10) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-08-10) - PSC08
-
capital-allotment-shares (2018-11-14) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-14) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-12-20) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-26) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-09) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-09) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-10) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-10) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-11-10) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-02) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date (2014-12-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-18) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-11-11) - RESOLUTIONS
-
legacy (2013-11-11) - SH20
-
legacy (2013-11-11) - CAP-SS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date (2013-11-26) - AR01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2013-11-11) - SH19
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-30) - AR01
-
legacy (2012-11-17) - MG01s
-
legacy (2012-10-25) - MG01s
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-10-11) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-15) - AD01
-
capital-allotment-shares (2012-05-17) - SH01
-
resolution (2012-05-17) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-20) - AP01
-
capital-allotment-shares (2012-04-16) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2012-04-16) - SH02
-
resolution (2012-04-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-31) - NEWINC