-
47 TRADE LTD. - Johnston Carmichael, 227 West George Street, Glasgow, G2 2ND, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC402624
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Johnston Carmichael
- 227 West George Street
- Glasgow
- G2 2ND Johnston Carmichael, 227 West George Street, Glasgow, G2 2ND UK
Management
- Geschäftsführung
- TOMKINS, Alan Cyril
- TOMKINS, Hazel Jane
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-29 12 Jahre
- SIC/NACE
- 56302
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alan Cyril Tomkins
- Mrs Hazel Jane Tomkins
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-06-30
- Letzte Einreichung: 2021-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-22
- Letzte Einreichung: 2023-03-08
-
47 TRADE LTD. Firmenbeschreibung
- 47 TRADE LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC402624. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.06.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56302" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Johnston Carmichael erreicht werden.
Jetzt sichern 47 TRADE LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 47 Trade Ltd. - Johnston Carmichael, 227 West George Street, Glasgow, G2 2ND, Grossbritannien
- 2011-06-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 47 TRADE LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-06-20) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-23) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-11) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-11) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-22) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-02) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2017-05-16) - 466(Scot)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-16) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-16) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-02) - AD01
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2017-06-08) - 466(Scot)
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2017-05-05) - 466(Scot)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-01) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-04) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-31) - AA
-
capital-allotment-shares (2016-01-28) - SH01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-29) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-07-06) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-09-12) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-07-04) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-07-04) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-06-30) - AP01
-
incorporation-company (2011-06-29) - NEWINC