-
HOLMES MILLER LTD. - 89 Minerva Street, Glasgow, G3 8LE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC400828
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 89 Minerva Street
- Glasgow
- G3 8LE 89 Minerva Street, Glasgow, G3 8LE UK
Management
- Geschäftsführung
- ELLSON, Mark Stuart
- GRAY, Timothy Robert
- HEAP, Craig
- HOLMES, Ryan Mervyn
- HOUSTON, Callum Mctaggart
- JACK, Douglas James
- KENNEDY, Robert Douglas
- LI, Ju
- MACLEAN, Alasdair Donald
- MCMILLAN, Alexander Ferguson
- YULE, Gareth Andrew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 02.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-02 13 Jahre
- SIC/NACE
- 71111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Callum Mctaggart Houston
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-06-02
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-27
- Letzte Einreichung: 2020-06-13
-
HOLMES MILLER LTD. Firmenbeschreibung
- HOLMES MILLER LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC400828. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 02.06.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71111" registriert. Das Unternehmen hat 11 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 02.06.2013.Die Firma kann schriftlich über 89 Minerva Street erreicht werden.
Jetzt sichern HOLMES MILLER LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Holmes Miller Ltd. - 89 Minerva Street, Glasgow, G3 8LE, Grossbritannien
- 2011-06-02
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HOLMES MILLER LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-04) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-06-15) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2020-07-10) - SH06
-
memorandum-articles (2020-07-10) - MA
-
resolution (2020-07-10) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2020-06-15) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-07-10) - SH03
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-03) - CS01
-
second-filing-capital-cancellation-shares (2020-08-11) - RP04SH06
-
capital-allotment-shares (2020-07-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
memorandum-articles (2019-04-30) - MA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-03) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-05-14) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2019-05-14) - SH06
-
capital-allotment-shares (2019-05-22) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-28) - TM01
-
resolution (2019-04-02) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-20) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-10-17) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-06) - CS01
-
resolution (2018-02-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-30) - CH01
-
capital-allotment-shares (2017-06-14) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-20) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type (2016-06-09) - RP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-08) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-08) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-24) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-09) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-01-12) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-01-31) - AA01
-
capital-allotment-shares (2012-02-09) - SH01
-
legacy (2012-03-22) - MG01s
-
legacy (2012-01-24) - MG01s
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-03-22) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-27) - AA
-
resolution (2012-02-09) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-12-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-06-09) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-06-09) - TM02
-
incorporation-company (2011-06-02) - NEWINC