-
KERLOCH OIL TOOLS LTD - Woodside Road, Bridge Of Don, Aberdeen, AB23 8EF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC395299
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Woodside Road
- Bridge Of Don
- Aberdeen
- AB23 8EF Woodside Road, Bridge Of Don, Aberdeen, AB23 8EF UK
Management
- Geschäftsführung
- FAUVEL, Melanie
- FAVRICHON, Stephane
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.03.2011
- Alter der Firma 2011-03-11 13 Jahre
- SIC/NACE
- 71129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Vallourec Oil & Gas Uk Ltd.
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CAIRNTOUL ENGINEERING LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-14
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
-
KERLOCH OIL TOOLS LTD Firmenbeschreibung
- KERLOCH OIL TOOLS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC395299. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.03.2011 registriert. KERLOCH OIL TOOLS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CAIRNTOUL ENGINEERING LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71129" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Woodside Road erreicht werden.
Jetzt sichern KERLOCH OIL TOOLS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kerloch Oil Tools Ltd - Woodside Road, Bridge Of Don, Aberdeen, AB23 8EF, Grossbritannien
- 2011-03-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KERLOCH OIL TOOLS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-06) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-06-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-28) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-12-29) - MR04
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-29) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-09) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-03-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-23) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-09) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-25) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-24) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-24) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-24) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-11-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-05) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-08-18) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-06-02) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-09-20) - AA
-
resolution (2013-07-22) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-15) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2013-02-18) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-10-09) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2012-06-07) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-26) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-04-15) - TM01
-
capital-allotment-shares (2011-05-26) - SH01
-
incorporation-company (2011-03-11) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-13) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-11-29) - AA01
-
legacy (2011-07-26) - MG01s
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-08-24) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-04-13) - AP03
-
resolution (2011-05-26) - RESOLUTIONS