-
NETWORK 90 LIMITED - 3 Clairmont Gardens, Glasgow, G3 7LW, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC390844
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Clairmont Gardens
- Glasgow
- G3 7LW
- Scotland 3 Clairmont Gardens, Glasgow, G3 7LW, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- MORRIS, Steven Charles
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-29 13 Jahre
- SIC/NACE
- 94990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Steven Charles Morris
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FORTY EIGHT SHELF (239) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-09
- Letzte Einreichung: 2019-12-29
-
NETWORK 90 LIMITED Firmenbeschreibung
- NETWORK 90 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC390844. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.12.2010 registriert. NETWORK 90 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FORTY EIGHT SHELF (239) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "94990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 3 Clairmont Gardens erreicht werden.
Jetzt sichern NETWORK 90 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Network 90 Limited - 3 Clairmont Gardens, Glasgow, G3 7LW, Scotland, Grossbritannien
- 2010-12-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NETWORK 90 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-09-14) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-07-18) - SH01
-
resolution (2018-07-18) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-08) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-28) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-08-22) - SH01
-
resolution (2017-08-22) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-18) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-07) - TM01
-
gazette-notice-compulsory (2016-12-13) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-12-24) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-16) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-07) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-09) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-02) - AA
-
capital-allotment-shares (2014-09-01) - SH01
-
resolution (2014-09-01) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
capital-allotment-shares (2013-11-20) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-09-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-21) - AP01
-
resolution (2013-07-17) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-07-17) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-07-17) - SH02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-10) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-06-22) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-09-05) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-10-16) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-10-16) - TM02
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-22) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-02-21) - AP03
-
termination-director-company-with-name (2011-02-18) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2011-02-18) - CERTNM
-
resolution (2011-02-18) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-29) - NEWINC