-
MOTIVE RENEWABLE ENERGY SERVICES LTD - Cairnton Road, Boyndie Drome, Banff, AB45 2LR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC387505
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cairnton Road
- Boyndie Drome
- Banff
- AB45 2LR Cairnton Road, Boyndie Drome, Banff, AB45 2LR UK
Management
- Geschäftsführung
- ACTON, David Edward
- GREGG, James Philip
- SLATTERY, Declan Joseph
- Prokuristen
- SLATTERY, Declan Joseph
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.10.2010
- Gelöscht am:
- 2024-01-02
- SIC/NACE
- 33190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Motive Offshore Group Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-22
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-28
- Letzte Einreichung: 2022-09-14
-
MOTIVE RENEWABLE ENERGY SERVICES LTD Firmenbeschreibung
- MOTIVE RENEWABLE ENERGY SERVICES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC387505. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.10.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "33190" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 22.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Cairnton Road erreicht werden.
Jetzt sichern MOTIVE RENEWABLE ENERGY SERVICES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Motive Renewable Energy Services Ltd - Cairnton Road, Boyndie Drome, Banff, AB45 2LR, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MOTIVE RENEWABLE ENERGY SERVICES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-voluntary (2024-01-02) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2023
-
gazette-notice-voluntary (2023-10-17) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-10-11) - DS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-09-14) - MR04
-
resolution (2022-07-19) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-07-14) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-01-18) - MR01
-
memorandum-articles (2022-07-19) - MA
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-12-22) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-08-09) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-29) - MR01
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2021-03-30) - 466(Scot)
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2020-12-15) - 466(Scot)
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-11-04) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-10) - MR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-11-04) - AP03
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2020-12-16) - 466(Scot)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-29) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-11-25) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-08-28) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-03-13) - AP03
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-07-16) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-10) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-06) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2017-07-18) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-15) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-18) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-07) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-02-21) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-20) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2015-02-20) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-06) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-19) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-02) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-08-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-25) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-10-22) - NEWINC