-
FARMER AUTOCARE NORTH LIMITED - Thain House, 226 Queensferry Road, Edinburgh, EH4 2BP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC378401
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Thain House
- 226 Queensferry Road
- Edinburgh
- EH4 2BP
- Scotland Thain House, 226 Queensferry Road, Edinburgh, EH4 2BP, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- DOLAN, Gregory James
- MCNEILL, Colin Fyffe
- MULVENNA, Andrew Graham
- Prokuristen
- MULVENNA, Andrew
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-12 14 Jahre
- SIC/NACE
- 45200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Sir Tom Farmer
- Sir Tom Farmer
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- CRAIG MILNE AUTOCARE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-04-30
- Letzte Einreichung: 2022-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-05-12
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-26
- Letzte Einreichung: 2023-05-12
-
FARMER AUTOCARE NORTH LIMITED Firmenbeschreibung
- FARMER AUTOCARE NORTH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC378401. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.05.2010 registriert. FARMER AUTOCARE NORTH LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CRAIG MILNE AUTOCARE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45200" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 12.05.2013.Die Firma kann schriftlich über Thain House erreicht werden.
Jetzt sichern FARMER AUTOCARE NORTH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Farmer Autocare North Limited - Thain House, 226 Queensferry Road, Edinburgh, EH4 2BP, Grossbritannien
- 2010-05-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FARMER AUTOCARE NORTH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-05-12) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-01-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-03-10) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-11-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-07-04) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-03-17) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-03-24) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-02-04) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-03-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-03-26) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-01) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-02-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-16) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-17) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-03-25) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-03-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-02-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-28) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-01-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
resolution (2011-03-24) - RESOLUTIONS
-
certificate-change-of-name-company (2011-03-24) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-10) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-03-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-05-12) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-06-14) - AA01
-
capital-allotment-shares (2010-06-14) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-06-14) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2010-06-14) - CERTNM
-
resolution (2010-06-14) - RESOLUTIONS