-
MUIR STREET DEVELOPMENTS LIMITED - Aviat House 4 Bell Drive, Hamilton Technology Park, Blantyre, G72 0FB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC377422
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Aviat House 4 Bell Drive
- Hamilton Technology Park
- Blantyre
- G72 0FB Aviat House 4 Bell Drive, Hamilton Technology Park, Blantyre, G72 0FB UK
Management
- Geschäftsführung
- PATERSON, John
- PATERSON, Mandy
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.04.2010
- Gelöscht am:
- 2020-07-23
- SIC/NACE
- 74990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Paterson
- Mr John Paterson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- MACNEWCO TWO HUNDRED AND NINETY EIGHT LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-23
-
MUIR STREET DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- MUIR STREET DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC377422. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.04.2010 registriert. MUIR STREET DEVELOPMENTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MACNEWCO TWO HUNDRED AND NINETY EIGHT LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Aviat House 4 Bell Drive erreicht werden.
Jetzt sichern MUIR STREET DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Muir Street Developments Limited - Aviat House 4 Bell Drive, Hamilton Technology Park, Blantyre, G72 0FB, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MUIR STREET DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-07-23) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting-scotland (2020-04-23) - LIQ13(Scot)
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-07-01) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-26) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-12) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-20) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-18) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-14) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-06-30) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
termination-director-company-with-name (2012-10-02) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-04-16) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-20) - AR01
-
resolution (2011-11-16) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2011-11-16) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-11-16) - TM02
-
capital-allotment-shares (2011-11-16) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-16) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2011-11-16) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-12-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2010-10-07) - TM01
-
incorporation-company (2010-04-23) - NEWINC