-
SITEKIT HEALTH LIMITED - 2 Broom Place, Portree, IV51 9HL, Scotland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC376978
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Broom Place
- Portree
- IV51 9HL
- Scotland 2 Broom Place, Portree, IV51 9HL, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- BIRSE, Scott Alexander
- BLOGG, Kevin Paul
- DE BENE, Jill Elizabeth
- ECKL, Christoph Franz Josef
- GRANT, Campbell Macleod
- GRANT, Kirsteen Shona
- WALKER, Robert James
- Prokuristen
- BIRSE, Scott Alexander
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.04.2010
- Alter der Firma 2010-04-16 14 Jahre
- SIC/NACE
- 62090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Sitekit Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-18
- Letzte Einreichung: 2023-04-04
-
SITEKIT HEALTH LIMITED Firmenbeschreibung
- SITEKIT HEALTH LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC376978. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.04.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62090" registriert. Das Unternehmen hat 7 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 2 Broom Place erreicht werden.
Jetzt sichern SITEKIT HEALTH LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sitekit Health Limited - 2 Broom Place, Portree, IV51 9HL, Scotland, Grossbritannien
- 2010-04-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SITEKIT HEALTH LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-12-27) - AA
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-03-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-30) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-13) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-30) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-06-13) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-06-13) - AP03
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-07-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-26) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-30) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-27) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-10) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-09-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-12-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-12-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-01-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2012-01-09) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-04-16) - NEWINC