-
SKIACK HYDRO LIMITED - 4 Melville Crescent, Edinburgh, EH3 7JA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC370147
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4 Melville Crescent
- Edinburgh
- EH3 7JA 4 Melville Crescent, Edinburgh, EH3 7JA UK
Management
- Geschäftsführung
- MUNRO, Finnian George
- WEMYSS, William John
- ORR, Martin
- Prokuristen
- WEMYSS, Isabella
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-15 14 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Finnian George Munro
- Wemyss Renewables Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-20
- Letzte Einreichung: 2021-02-06
-
SKIACK HYDRO LIMITED Firmenbeschreibung
- SKIACK HYDRO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC370147. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.12.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4 Melville Crescent erreicht werden.
Jetzt sichern SKIACK HYDRO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Skiack Hydro Limited - 4 Melville Crescent, Edinburgh, EH3 7JA, Grossbritannien
- 2009-12-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SKIACK HYDRO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-03-15) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-24) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-12-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-03-17) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-02-02) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-02) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-09-04) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-09-04) - SH08
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-17) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-18) - TM01
-
resolution (2015-09-04) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-18) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-06-10) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-18) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-09-18) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-11-05) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-25) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-27) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-19) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-01-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-16) - AA
-
capital-allotment-shares (2011-07-21) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-07-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-name-of-class-of-shares (2010-11-16) - SH08
-
resolution (2010-11-16) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-11-16) - AP01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2010-11-16) - AP04
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-12-29) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-12-29) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-29) - AR01
-
capital-allotment-shares (2010-11-18) - SH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-15) - NEWINC