-
TRITON SOFTWARE LTD - 13 Queen's Road, Aberdeen, AB15 4YL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC366013
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 13 Queen's Road
- Aberdeen
- AB15 4YL 13 Queen's Road, Aberdeen, AB15 4YL UK
Management
- Geschäftsführung
- KINGS, Andrew Frederick
- SHAPIRO, Jonathan Mark
- JOSHI, Bhuwan Chand
- Prokuristen
- PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.09.2009
- Alter der Firma 2009-09-23 14 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Jonathan Mark Shapiro
- Carolyn Shapiro
- Jonathan Mark Shapiro
- Carolyn Shapiro
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- PISYS MARINE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-10-31
- Letzte Einreichung: 2022-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-10
- Letzte Einreichung: 2023-09-26
-
TRITON SOFTWARE LTD Firmenbeschreibung
- TRITON SOFTWARE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC366013. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.09.2009 registriert. TRITON SOFTWARE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PISYS MARINE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.01.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.09.2012.Die Firma kann schriftlich über 13 Queen's Road erreicht werden.
Jetzt sichern TRITON SOFTWARE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Triton Software Ltd - 13 Queen's Road, Aberdeen, AB15 4YL, Grossbritannien
- 2009-09-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRITON SOFTWARE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-30) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2023-02-17) - CERTNM
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-15) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-20) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-11-15) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-29) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-14) - AA
-
memorandum-articles (2013-06-18) - MEM/ARTS
-
resolution (2013-06-18) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2013-06-18) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2013-06-18) - SH06
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-10-30) - AA
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2012-08-15) - AP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-28) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-15) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-08-15) - TM02
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-24) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-01-12) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-15) - AR01
-
capital-allotment-shares (2010-02-18) - SH01
-
certificate-change-of-name-company (2010-02-03) - CERTNM
-
resolution (2010-02-03) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-24) - AP01
-
capital-allotment-shares (2009-12-24) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2009-12-24) - TM01
-
incorporation-company (2009-09-23) - NEWINC