-
GLASGOW WATERLOO STREET HOTEL (TRADING) LIMITED - MAVEN CAPITAL PARTNERS UK LLP, Kintyre House, 205 West George Street, Glasgow, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC363249
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- MAVEN CAPITAL PARTNERS UK LLP
- Kintyre House
- 205 West George Street
- Glasgow
- G2 2LW MAVEN CAPITAL PARTNERS UK LLP, Kintyre House, 205 West George Street, Glasgow, G2 2LW UK
Management
- Geschäftsführung
- COLLIS, Michael Christopher
- DUFF, George Ramsay
- Prokuristen
- MAVEN CAPITAL PARTNERS UK LLP
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.07.2009
- Gelöscht am:
- 2021-10-26
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Hdf General Partners Ii Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- GLASGOW INDIGO HOTEL (TRADING) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-08-12
- Letzte Einreichung: 2021-07-29
-
GLASGOW WATERLOO STREET HOTEL (TRADING) LIMITED Firmenbeschreibung
- GLASGOW WATERLOO STREET HOTEL (TRADING) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC363249. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 29.07.2009 registriert. GLASGOW WATERLOO STREET HOTEL (TRADING) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GLASGOW INDIGO HOTEL (TRADING) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 29.07.2012.Die Firma kann schriftlich über Maven Capital Partners Uk Llp erreicht werden.
Jetzt sichern GLASGOW WATERLOO STREET HOTEL (TRADING) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Glasgow Waterloo Street Hotel (Trading) Limited - MAVEN CAPITAL PARTNERS UK LLP, Kintyre House, 205 West George Street, Glasgow, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GLASGOW WATERLOO STREET HOTEL (TRADING) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2021-03-24) - CH04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-29) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-08-03) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-08-10) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-02) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-01) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-01) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-01) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-03-13) - AP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-08-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
certificate-change-of-name-company (2014-05-02) - CERTNM
-
resolution (2014-05-02) - RESOLUTIONS
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2014-05-16) - 466(Scot)
-
mortgage-alter-floating-charge-with-number (2014-05-21) - 466(Scot)
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-05-02) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-08-19) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-09-01) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-05-09) - MR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-08-15) - TM02
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-12-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-25) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-08-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-08-07) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2013-08-06) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-07-02) - DISS40
-
auditors-resignation-company (2013-05-08) - AUD
-
gazette-notice-compulsory (2013-04-19) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-21) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2012-05-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-03-24) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2011-05-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-08-26) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-08-26) - CH04
-
legacy (2010-04-07) - MG01s
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-08-14) - 288a
-
certificate-change-of-name-company (2009-08-08) - CERTNM
-
legacy (2009-08-07) - 288b
-
incorporation-company (2009-07-29) - NEWINC