-
DIGITAL I.T. AND COMMUNICATIONS (SCOTLAND) LIMITED - C/O Leonard Curtis Recovery Limited Fourth Floor, 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC339399
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Leonard Curtis Recovery Limited Fourth Floor
- 58 Waterloo Street
- Glasgow
- G2 7DA C/O Leonard Curtis Recovery Limited Fourth Floor, 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA UK
Management
- Geschäftsführung
- ARMSTRONG, Craig
- MCDONALD, Thomas
- STEWART, Hugh
- WARDLAW, John Robert
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.03.2008
- Gelöscht am:
- 2023-01-20
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Hugh Stewart
- Mr John Stewart
- Coralinn Llp
- Mr Hugh Stewart
- Mr John Stewart
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- EXSEL I.T. AND COMMUNICATIONS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-12-31
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-03-25
- Letzte Einreichung: 2018-03-11
-
DIGITAL I.T. AND COMMUNICATIONS (SCOTLAND) LIMITED Firmenbeschreibung
- DIGITAL I.T. AND COMMUNICATIONS (SCOTLAND) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC339399. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.03.2008 registriert. DIGITAL I.T. AND COMMUNICATIONS (SCOTLAND) LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen EXSEL I.T. AND COMMUNICATIONS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.03.2013.Die Firma kann schriftlich über C/o Leonard Curtis Recovery Limited Fourth Floor erreicht werden.
Jetzt sichern DIGITAL I.T. AND COMMUNICATIONS (SCOTLAND) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Digital I.t. And Communications (Scotland) Limited - C/O Leonard Curtis Recovery Limited Fourth Floor, 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DIGITAL I.T. AND COMMUNICATIONS (SCOTLAND) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-09) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-01) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-08) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-11) - MR04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-12) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-12) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-11) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-12) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-21) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-31) - MR01
-
resolution (2018-06-05) - RESOLUTIONS
-
liquidation-compulsory-appointment-provisional-liquidator-scotland (2018-06-18) - 4.9(Scot)
-
liquidation-compulsory-winding-up-order-scotland (2018-07-09) - 4.2(Scot)
-
liquidation-compulsory-notice-winding-up-scotland (2018-07-09) - CO4.2(Scot)
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-12) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-23) - MR01
-
resolution (2017-01-19) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-01-16) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-27) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-10) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-11) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-17) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-05-06) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2014-05-06) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-05) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-18) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-17) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
incorporation-company (2008-03-11) - NEWINC