-
MILLER HOMES CAMBUSLANG LIMITED - Miller House 2 Lochside View, Edinburgh Park, Edinburgh, Midlothian, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC337900
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Miller House 2 Lochside View
- Edinburgh Park
- Edinburgh
- Midlothian
- EH12 9DH Miller House 2 Lochside View, Edinburgh Park, Edinburgh, Midlothian, EH12 9DH UK
Management
- Geschäftsführung
- JACKSON, Julie Mansfield
- MURDOCH, Ian
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.02.2008
- Alter der Firma 2008-02-15 16 Jahre
- SIC/NACE
- 41201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Miller Homes Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MM&S (5347) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-03-15
- Letzte Einreichung: 2020-03-01
-
MILLER HOMES CAMBUSLANG LIMITED Firmenbeschreibung
- MILLER HOMES CAMBUSLANG LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC337900. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.02.2008 registriert. MILLER HOMES CAMBUSLANG LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MM&S (5347) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41201" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Miller House 2 Lochside View erreicht werden.
Jetzt sichern MILLER HOMES CAMBUSLANG LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Miller Homes Cambuslang Limited - Miller House 2 Lochside View, Edinburgh Park, Edinburgh, Midlothian, Grossbritannien
- 2008-02-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MILLER HOMES CAMBUSLANG LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-04) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-09-24) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-09-25) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-23) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-06-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-06-17) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-12-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-06) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-18) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-05-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2012-10-31) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-07-05) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2012-05-30) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-03-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-09-29) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-09-28) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-04-26) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-02) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-03-02) - CH03
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-05-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-03-06) - 288a
-
legacy (2009-03-30) - 288b
-
legacy (2009-04-02) - 288b
-
legacy (2009-02-19) - 288b
-
legacy (2009-05-12) - 225
-
accounts-with-accounts-type-full (2009-08-24) - AA
-
legacy (2009-04-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-06-12) - 410(Scot)
-
legacy (2008-06-04) - 410(Scot)
-
legacy (2008-05-12) - 288a
-
legacy (2008-05-09) - 288a
-
legacy (2008-05-09) - 288b
-
legacy (2008-04-17) - 287
-
certificate-change-of-name-company (2008-04-14) - CERTNM
-
incorporation-company (2008-02-15) - NEWINC