-
PRISM RESIDENTIAL (SCOTLAND) LIMITED - 63 English Street, Dumfries, DG1 2DA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC329107
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 63 English Street
- Dumfries
- DG1 2DA 63 English Street, Dumfries, DG1 2DA UK
Management
- Geschäftsführung
- MARSHALL, Raymond
- RUSSELL, Stephen
- Prokuristen
- RUSSELL, Stephen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.08.2007
- Gelöscht am:
- 2023-06-20
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Raymond Marshall
- Mr Raymond Marshall
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-24
- Letzte Einreichung: 2020-08-10
-
PRISM RESIDENTIAL (SCOTLAND) LIMITED Firmenbeschreibung
- PRISM RESIDENTIAL (SCOTLAND) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC329107. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.08.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 63 English Street erreicht werden.
Jetzt sichern PRISM RESIDENTIAL (SCOTLAND) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Prism Residential (Scotland) Limited - 63 English Street, Dumfries, DG1 2DA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRISM RESIDENTIAL (SCOTLAND) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-03-27) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2023-04-04) - GAZ1(A)
-
gazette-dissolved-voluntary (2023-06-20) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2022
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2022-01-13) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-19) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-05-12) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-19) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-27) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-27) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-27) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-25) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-07-25) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-09-05) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-26) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-12-24) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2016-11-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-04) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-14) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-09-02) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-12-02) - CH01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-17) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-18) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-07-02) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-02-06) - 288a
-
legacy (2008-07-15) - 410(Scot)
-
legacy (2008-09-19) - 88(2)
-
legacy (2008-09-19) - 225
-
legacy (2008-12-22) - 288c
-
legacy (2008-12-22) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-05) - 288b
-
legacy (2007-11-05) - 288a
-
legacy (2007-12-27) - 410(Scot)
-
incorporation-company (2007-08-10) - NEWINC