-
TRIMSECRETS LIMITED - Burnfield House, 4a Burnfield Avenue, Glasgow, G46 7TL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC310020
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Burnfield House
- 4a Burnfield Avenue
- Glasgow
- G46 7TL
- United Kingdom Burnfield House, 4a Burnfield Avenue, Glasgow, G46 7TL, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- MONE, Rebecca Frances
- WILSON, Rory Grant Adam
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.10.2006
- Gelöscht am:
- 2021-09-14
- SIC/NACE
- 46900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Miss Rebecca Frances Mone
- Mr Tony Caplan
- Mr Tony Caplan
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-01-31
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-10-25
- Letzte Einreichung: 2019-10-11
-
TRIMSECRETS LIMITED Firmenbeschreibung
- TRIMSECRETS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC310020. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.10.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.10.2012.Die Firma kann schriftlich über Burnfield House erreicht werden.
Jetzt sichern TRIMSECRETS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trimsecrets Limited - Burnfield House, 4a Burnfield Avenue, Glasgow, G46 7TL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRIMSECRETS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-29) - GAZ1
-
gazette-dissolved-compulsory (2021-09-14) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-06-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-21) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-09-03) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-09-30) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-09-24) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-12-31) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name (2013-02-26) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-31) - AR01
-
resolution (2013-02-26) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name (2013-02-26) - TM01
-
statement-of-companys-objects (2013-02-26) - CC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-06) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-01-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-05) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-04) - 363a
-
legacy (2008-11-04) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-04-08) - AA
-
legacy (2008-01-08) - 225
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-24) - 363a
-
legacy (2007-10-24) - 287
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-10-11) - NEWINC