-
DELIVERING CHOICE LIMITED - Yewbank, Coupar Angus Road, Blairgowrie, PH10 6JY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC273024
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Yewbank
- Coupar Angus Road
- Blairgowrie
- PH10 6JY
- Scotland Yewbank, Coupar Angus Road, Blairgowrie, PH10 6JY, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.09.2004
- Gelöscht am:
- 2020-09-22
- SIC/NACE
- 69203
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Roy Walter Mcintosh Coles
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ROY COLES ACCOUNTING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2018-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-07
-
DELIVERING CHOICE LIMITED Firmenbeschreibung
- DELIVERING CHOICE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC273024. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.09.2004 registriert. DELIVERING CHOICE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ROY COLES ACCOUNTING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69203" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Yewbank erreicht werden.
Jetzt sichern DELIVERING CHOICE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Delivering Choice Limited - Yewbank, Coupar Angus Road, Blairgowrie, PH10 6JY, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DELIVERING CHOICE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-09-22) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
dissolution-application-strike-off-company (2019-07-30) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2019-08-06) - GAZ1(A)
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-12-11) - MR04
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2019-09-07) - SOAS(A)
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-07-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-11-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-08) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-14) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-04-07) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-01) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-12-01) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-04-14) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-08-03) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-27) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-06-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-10) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-08) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-01-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
capital-return-purchase-own-shares (2010-10-29) - SH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-30) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-03-12) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2010-03-11) - CERTNM
-
resolution (2010-03-11) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-10) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-02-27) - AA
-
legacy (2008-07-17) - 169
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-08-04) - AA
-
legacy (2008-09-11) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-07) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-09-11) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-10-25) - AA
-
legacy (2005-09-07) - 363a
-
legacy (2005-06-01) - 88(2)R
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-11-05) - 410(Scot)
-
legacy (2004-09-21) - 225
-
legacy (2004-09-09) - 288b
-
incorporation-company (2004-09-07) - NEWINC