-
COLLINGBOURNE HENNAH LAW LLP - 13 Clytha Park Road, Newport, NP20 4PB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- OC353053
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 13 Clytha Park Road
- Newport
- NP20 4PB 13 Clytha Park Road, Newport, NP20 4PB UK
Firmendetails
- Geschäftszweig
- llp
- Gründungsdatum
- 09.03.2010
- Alter der Firma 2010-03-09 14 Jahre
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nathan John Hennah
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HORNBY BAKER JONES & WOOD LAW LLP
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-23
- Letzte Einreichung: 2021-03-09
-
COLLINGBOURNE HENNAH LAW LLP Firmenbeschreibung
- COLLINGBOURNE HENNAH LAW LLP ist eine in Grossbritannien als llp registrierte Firma mit der Register-Nr. OC353053. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.03.2010 registriert. COLLINGBOURNE HENNAH LAW LLP hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HORNBY BAKER JONES & WOOD LAW LLP ausgeführt. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 13 Clytha Park Road erreicht werden.
Jetzt sichern COLLINGBOURNE HENNAH LAW LLP HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Collingbourne Hennah Law Llp - 13 Clytha Park Road, Newport, NP20 4PB, Grossbritannien
- 2010-03-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COLLINGBOURNE HENNAH LAW LLP aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-notice-voluntary (2021-09-14) - GAZ1(A)
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-19) - LLCS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control-limited-liability-partnership (2021-04-19) - LLPSC07
-
dissolution-application-strike-off-limited-liability-partnership (2021-09-07) - LLDS01
-
gazette-notice-compulsory (2021-09-07) - GAZ1
-
termination-member-limited-liability-partnership-with-name-termination-date (2021-04-19) - LLTM01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-17) - LLCS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-05) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full-limited-liability-partnership (2019-06-24) - LLMR04
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-06-15) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-28) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-14) - LLCS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full-limited-liability-partnership (2018-07-25) - LLMR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-13) - LLCS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-limited-liability-partnership-previous-extended (2017-12-19) - LLAA01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-28) - LLCS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
annual-return-limited-liability-partnership-with-made-up-date (2016-03-22) - LLAR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-17) - AA
-
termination-member-limited-liability-partnership-with-name-termination-date (2015-08-27) - LLTM01
-
annual-return-limited-liability-partnership-with-made-up-date (2015-04-09) - LLAR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-02) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-17) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-limited-liability-partnership-with-made-up-date (2014-04-14) - LLAR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-06) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-member-limited-liability-partnership-with-name (2013-11-08) - LLTM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-04-06) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-05) - AA
-
annual-return-limited-liability-partnership-with-made-up-date (2013-04-04) - LLAR01
-
gazette-notice-compulsary (2013-04-02) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-limited-liability-partnership-with-made-up-date (2012-05-04) - LLAR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-06) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-account-reference-date-limited-liability-partnership-previous-shortened (2011-12-07) - LLAA01
-
legacy (2011-08-10) - LLMG01
-
termination-member-limited-liability-partnership-with-name (2011-06-10) - LLTM01
-
termination-member-limited-liability-partnership-with-name (2011-04-20) - LLTM01
-
annual-return-limited-liability-partnership-with-made-up-date (2011-04-15) - LLAR01
-
change-account-reference-date-limited-liability-partnership-current-extended (2011-01-10) - LLAA01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-05-11) - LLMG01
-
appoint-corporate-member-limited-liability-partnership (2010-04-16) - LLAP02
-
incorporation-limited-liability-partnership (2010-03-09) - LLIN01