-
CENTRAL FUSION LIMITED - Central Fusion Limited, Innovation Centre, Queens Road, Belfast, BT3 9DT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI641970
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Central Fusion Limited, Innovation Centre
- Queens Road
- Belfast
- BT3 9DT
- Northern Ireland Central Fusion Limited, Innovation Centre, Queens Road, Belfast, BT3 9DT, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- IRWIN, Richard Stephen
- SYMINGTON, Stephen Brian
- CURTIS-POWLEY, Thomas Oliver
- MOEN, Niall James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.11.2016
- Alter der Firma 2016-11-04 7 Jahre
- SIC/NACE
- 56210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Norlin Ventures Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- CENTRAL CATERING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-13
- Letzte Einreichung: 2023-04-29
-
CENTRAL FUSION LIMITED Firmenbeschreibung
- CENTRAL FUSION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI641970. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.11.2016 registriert. CENTRAL FUSION LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CENTRAL CATERING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56210" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Central Fusion Limited, Innovation Centre erreicht werden.
Jetzt sichern CENTRAL FUSION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Central Fusion Limited - Central Fusion Limited, Innovation Centre, Queens Road, Belfast, BT3 9DT, Grossbritannien
- 2016-11-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CENTRAL FUSION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2024-04-23) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-04-23) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2024-04-24) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-04-24) - MR04
keyboard_arrow_right 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-11-07) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-11-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-06-15) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-11-22) - DISS40
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-04-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-13) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-01-10) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-01-10) - PSC05
keyboard_arrow_right 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-04-01) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-19) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-09) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-11-10) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2020-07-16) - MR05
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-29) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-09-07) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-17) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-09-14) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-14) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-04-16) - MR01
-
memorandum-articles (2019-03-22) - MA
-
resolution (2019-03-12) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-11) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-02-26) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-21) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-07) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-14) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charles-court-order-extend-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-08) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-06) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-09) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-09) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-12) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-07-12) - PSC05
-
resolution (2017-06-05) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-08) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-07) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-12-07) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-07) - AP01
-
incorporation-company (2016-11-04) - NEWINC