-
POUNDBRIDGE GREEN LTD - 41-43 Waring Street, Belfast, BT1 2DY, Northern Ireland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI634751
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 41-43 Waring Street
- Belfast
- BT1 2DY
- Northern Ireland 41-43 Waring Street, Belfast, BT1 2DY, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- MARSHALL, David Frederick
- ROYAL, Leza Dawn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.11.2015
- Alter der Firma 2015-11-10 8 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr David Frederick Marshall
- Mr Colin Torquil Sandy
- Feastivals For Fun Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- RISSMO ENERGY LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-27
- Letzte Einreichung: 2022-06-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-23
- Letzte Einreichung: 2023-06-09
-
POUNDBRIDGE GREEN LTD Firmenbeschreibung
- POUNDBRIDGE GREEN LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI634751. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 10.11.2015 registriert. POUNDBRIDGE GREEN LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RISSMO ENERGY LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 41-43 Waring Street erreicht werden.
Jetzt sichern POUNDBRIDGE GREEN LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Poundbridge Green Ltd - 41-43 Waring Street, Belfast, BT1 2DY, Northern Ireland, Grossbritannien
- 2015-11-10
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu POUNDBRIDGE GREEN LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-03-04) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2024-03-12) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-02-27) - MR04
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-06-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-09) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2022-06-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-04-08) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-06-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-10) - CS01
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2020-10-06) - MR05
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-07-31) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-24) - AA01
-
capital-cancellation-shares (2019-07-05) - SH06
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-18) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-06-18) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-16) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-09) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-01) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-01) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-09) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-09) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-12) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-27) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-26) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-09) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-20) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-04) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-07) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2016-01-07) - CERTNM
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-08) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-02-04) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-01) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-07) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-07-19) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-11-10) - NEWINC