-
CHIEFTAIN FLEET MANAGEMENT LIMITED - 32, Lodge Road, Coleraine, BT52 1NB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI623682
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 32
- Lodge Road
- Coleraine
- BT52 1NB
- Northern Ireland 32, Lodge Road, Coleraine, BT52 1NB, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- COX, David Norman
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 77120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Town Head Estate Limited
- Oakfield Manor Estates Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- CHIEFTAN LOGISTICS LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-27
- Letzte Einreichung: 2020-11-13
-
CHIEFTAIN FLEET MANAGEMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- CHIEFTAIN FLEET MANAGEMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI623682. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.03.2014 registriert. CHIEFTAIN FLEET MANAGEMENT LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CHIEFTAN LOGISTICS LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77120" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 32 erreicht werden.
Jetzt sichern CHIEFTAIN FLEET MANAGEMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Chieftain Fleet Management Limited - 32, Lodge Road, Coleraine, BT52 1NB, Grossbritannien
- 2014-03-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHIEFTAIN FLEET MANAGEMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-01) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-13) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-11-13) - PSC05
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-13) - PSC02
-
capital-allotment-shares (2019-11-13) - SH01
-
resolution (2019-10-28) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-18) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-16) - AP01
-
resolution (2019-08-21) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-06) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-03) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-10) - PSC05
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-05) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-05) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-31) - PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-29) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-11) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-11) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-06) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-06) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-14) - AP01
-
incorporation-company (2014-03-27) - NEWINC