-
ASP FLEXIBLES LIMITED - C/O Webtech (Ni) Ltd, Killyhevlin Industrial Estate, Enniskillen, BT74 4EJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI613785
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Webtech (Ni) Ltd
- Killyhevlin Industrial Estate
- Enniskillen
- BT74 4EJ C/O Webtech (Ni) Ltd, Killyhevlin Industrial Estate, Enniskillen, BT74 4EJ UK
Management
- Geschäftsführung
- BALET, Angel Ramon Alejandro
- BALET, Susana Alejandro
- BANKS, Simon
- Prokuristen
- KRALEV, Jonathan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.07.2012
- Alter der Firma 2012-07-30 11 Jahre
- SIC/NACE
- 22220
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Americk (Ni) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GELLAW 333 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-04-30
- Letzte Einreichung: 2022-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-18
- Letzte Einreichung: 2023-05-04
-
ASP FLEXIBLES LIMITED Firmenbeschreibung
- ASP FLEXIBLES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI613785. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.07.2012 registriert. ASP FLEXIBLES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GELLAW 333 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "22220" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über C/o Webtech (Ni) Ltd erreicht werden.
Jetzt sichern ASP FLEXIBLES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Asp Flexibles Limited - C/O Webtech (Ni) Ltd, Killyhevlin Industrial Estate, Enniskillen, BT74 4EJ, Grossbritannien
- 2012-07-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ASP FLEXIBLES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-16) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-07-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-07-20) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-09-02) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2022-09-16) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-09-16) - TM02
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-09-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-08-12) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-07) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-05) - MR04
-
capital-allotment-shares (2018-07-31) - SH01
-
resolution (2018-07-31) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-05-10) - AA
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-07-31) - SH19
-
legacy (2018-07-31) - SH20
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-01) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-09-08) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-11) - AA
-
legacy (2018-07-31) - CAP-SS
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-19) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-11-15) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-05) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-19) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-30) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-part (2016-08-02) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-23) - CS01
-
auditors-resignation-company (2016-08-05) - AUD
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-04) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-02) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-23) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-medium (2015-09-17) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-14) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-16) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-18) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-10-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-01) - AR01
-
resolution (2014-02-26) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-02-26) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-10-01) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-09-25) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-22) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-01-10) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-07-30) - NEWINC
-
legacy (2012-12-27) - MG01
-
legacy (2012-10-17) - MG01
-
certificate-change-of-name-company (2012-08-08) - CERTNM