-
IRISH MANUFACTURING SERVICES LIMITED - 34a Dunroe Road, Clogher, County Tyrone, BT76 0DZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI603583
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 34a Dunroe Road
- Clogher
- County Tyrone
- BT76 0DZ
- Northern Ireland 34a Dunroe Road, Clogher, County Tyrone, BT76 0DZ, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- KELLY, Brian Peter
- MCMEEL, Patrick Gerard
- WARD, Paul
- Prokuristen
- MCMEEL, Patrick Gerard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.06.2010
- Alter der Firma 2010-06-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 28921
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Brian Peter Kelly
- Mr Paul Ward
- Mr Patrick Gerard Mcmeel
- Mr Paul Ward
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- IRISH MANFACTURING SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-06-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-03
- Letzte Einreichung: 2020-06-19
-
IRISH MANUFACTURING SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- IRISH MANUFACTURING SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI603583. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.06.2010 registriert. IRISH MANUFACTURING SERVICES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen IRISH MANFACTURING SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "28921" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.06.2013.Die Firma kann schriftlich über 34A Dunroe Road erreicht werden.
Jetzt sichern IRISH MANUFACTURING SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Irish Manufacturing Services Limited - 34a Dunroe Road, Clogher, County Tyrone, BT76 0DZ, Grossbritannien
- 2010-06-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu IRISH MANUFACTURING SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-03-02) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-03-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-07) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-05-23) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-07-07) - AP03
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-04-02) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-audited-abridged (2018-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-28) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-28) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-07-10) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-25) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-08) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-25) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-06-28) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-06-27) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-27) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-06-27) - CH03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-05-13) - AA01
-
legacy (2011-03-23) - MG01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-03-15) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-11-12) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2010-09-28) - CERTNM
-
incorporation-company (2010-06-23) - NEWINC
-
change-of-name-notice (2010-09-20) - CONNOT