-
JC PATTERSON LIMITED - C/O BDO NORTHERN IRELAND, Lindsay House, 10 Callender Street, Belfast, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI601588
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O BDO NORTHERN IRELAND
- Lindsay House
- 10 Callender Street
- Belfast
- BT1 5BN
- Northern Ireland C/O BDO NORTHERN IRELAND, Lindsay House, 10 Callender Street, Belfast, BT1 5BN, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- PATTERSON, Hamilton Smyth
- ROLSTON, Hazel Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2009
- Gelöscht am:
- 2022-01-18
- SIC/NACE
- 47540
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Meta Patterson
- Hamilton Smyth Patterson
- Mrs Hazel Elizabeth Rolston
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-29
- Letzte Einreichung: 2020-10-15
-
JC PATTERSON LIMITED Firmenbeschreibung
- JC PATTERSON LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI601588. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 11.12.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47540" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 11.12.2012.Die Firma kann schriftlich über C/o Bdo Northern Ireland erreicht werden.
Jetzt sichern JC PATTERSON LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jc Patterson Limited - C/O BDO NORTHERN IRELAND, Lindsay House, 10 Callender Street, Belfast, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JC PATTERSON LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
gazette-dissolved-voluntary (2022-01-18) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2021
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-10-27) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-11-02) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-11-26) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-26) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-22) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-23) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-23) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-23) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-18) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-02) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-02) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-09) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-25) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-23) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-12-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-04-01) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
termination-director-company-with-name (2010-02-16) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-17) - AR01
-
resolution (2010-10-20) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2010-10-15) - SH02
-
resolution (2010-10-15) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2010-10-15) - SH01
-
resolution (2010-03-22) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2010-02-16) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-02-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-11) - NEWINC