-
CAR PARTS OUTLET STORE LIMITED - Suite 152 21 Botanic Avenue, Belfast, BT7 1JG, Northern Ireland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI074076
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 152 21 Botanic Avenue
- Belfast
- BT7 1JG
- Northern Ireland Suite 152 21 Botanic Avenue, Belfast, BT7 1JG, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- LARKIN, Damien
- LARKIN, Gary
- Prokuristen
- LARKIN, Gary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.09.2009
- Alter der Firma 2009-09-30 14 Jahre
- SIC/NACE
- 45320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Gary Larkin
- Ms. Seanine Mcconnell
- Ms. Seanine Mcconnell
- -
- Mr Gary Larkin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- AUTO BITS DISCOUNT SHOP LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-21
- Letzte Einreichung: 2020-09-07
-
CAR PARTS OUTLET STORE LIMITED Firmenbeschreibung
- CAR PARTS OUTLET STORE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI074076. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.09.2009 registriert. CAR PARTS OUTLET STORE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AUTO BITS DISCOUNT SHOP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45320" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 30.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Suite 152 21 Botanic Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern CAR PARTS OUTLET STORE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Car Parts Outlet Store Limited - Suite 152 21 Botanic Avenue, Belfast, BT7 1JG, Northern Ireland, Grossbritannien
- 2009-09-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAR PARTS OUTLET STORE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-09-27) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-10) - AD01
-
resolution (2019-07-08) - RESOLUTIONS
-
change-of-name-notice (2019-06-25) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-11) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2017-02-06) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-02-06) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-21) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-04-04) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-04) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-14) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-14) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-04-04) - AP03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-14) - PSC07
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-09-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-06-22) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-06-10) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-26) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2013-06-13) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-01-06) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-03-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-12-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-23) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-12-14) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2011-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
termination-secretary-company-with-name (2009-11-28) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-11-28) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2009-11-28) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2009-11-28) - AP03
-
incorporation-company (2009-09-30) - NEWINC