-
MOURNE RECYCLING LTD - 35 Barron Road, Dunamanagh, Strabane, BT82 0JD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI073541
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 35 Barron Road
- Dunamanagh
- Strabane
- BT82 0JD
- Northern Ireland 35 Barron Road, Dunamanagh, Strabane, BT82 0JD, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- MCGERRIGLE, George
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.08.2009
- Alter der Firma 2009-08-19 14 Jahre
- SIC/NACE
- 38210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Colm Lafferty
- Mr George Mcgerrigle
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-19
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-05
- Letzte Einreichung: 2021-02-19
-
MOURNE RECYCLING LTD Firmenbeschreibung
- MOURNE RECYCLING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI073541. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "38210" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 19.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 35 Barron Road erreicht werden.
Jetzt sichern MOURNE RECYCLING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mourne Recycling Ltd - 35 Barron Road, Dunamanagh, Strabane, BT82 0JD, Grossbritannien
- 2009-08-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MOURNE RECYCLING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-04-03) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-04-03) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-20) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-05-18) - TM02
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-09-04) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-09-03) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-09-02) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-16) - PSC04
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-07-05) - AP03
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
gazette-notice-compulsory (2018-07-31) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-20) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-08-21) - DISS40
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-22) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-09) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-09) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-09) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-30) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-13) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-26) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-20) - TM01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-22) - AAMD
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-28) - AA
-
accounts-amended-with-made-up-date (2014-04-15) - AAMD
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-31) - AA
-
termination-director-company-with-name (2013-08-06) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-08-15) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-19) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-08-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-20) - AR01
-
accounts-amended-with-made-up-date (2011-08-17) - AAMD
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-19) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-11-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-11-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-03) - 296(NI)
-
incorporation-company (2009-08-19) - NEWINC