-
CUSHER VIEW LIMITED - 2 Old Scarva Road, Tandragee, Craigavon, County Armagh, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI066694
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2 Old Scarva Road
- Tandragee
- Craigavon
- County Armagh
- BT62 2ED 2 Old Scarva Road, Tandragee, Craigavon, County Armagh, BT62 2ED UK
Management
- Geschäftsführung
- SCULLION, Adrian
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.10.2007
- Gelöscht am:
- 2020-09-22
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Thomas Bullivant
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- LISDOONVARNA LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-10-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-01
- Letzte Einreichung: 2019-10-18
-
CUSHER VIEW LIMITED Firmenbeschreibung
- CUSHER VIEW LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI066694. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 18.10.2007 registriert. CUSHER VIEW LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LISDOONVARNA LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.10.2012.Die Firma kann schriftlich über 2 Old Scarva Road erreicht werden.
Jetzt sichern CUSHER VIEW LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cusher View Limited - 2 Old Scarva Road, Tandragee, Craigavon, County Armagh, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CUSHER VIEW LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-09-22) - GAZ2(A)
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-20) - TM01
-
gazette-notice-voluntary (2020-04-07) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-03-26) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-08) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-02) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-01-27) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-12) - AR01
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2015-12-10) - MR05
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-13) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-02) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-22) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-10-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-24) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-secretary-company-with-name (2011-08-15) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-11-11) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-10) - CH01
-
move-registers-to-sail-company (2009-11-10) - AD03
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2009-11-10) - CH03
-
change-sail-address-company (2009-11-09) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-11-09) - CH01
-
legacy (2009-03-08) - 233(NI)
keyboard_arrow_right 2008
-
particulars-of-a-mortgage-charge (2008-01-22) - 402(NI)
-
resolution (2008-02-27) - RESOLUTIONS
-
resolution (2008-02-06) - RESOLUTIONS
-
legacy (2008-07-08) - 296(NI)
-
legacy (2008-11-12) - 371S(NI)
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-21) - 98-2(NI)
-
resolution (2007-11-15) - RESOLUTIONS
-
legacy (2007-11-15) - 296(NI)
-
legacy (2007-11-15) - 295(NI)
-
legacy (2007-11-15) - UDM+A(NI)
-
legacy (2007-10-31) - CNRES(NI)
-
incorporation-company (2007-10-18) - NEWINC
-
legacy (2007-10-31) - CERTC(NI)