-
A-ONE CONTROL SYSTEMS LIMITED - Unit 24, Scarva Road Industrial Estate, Banbridge, County Down, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI066242
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 24
- Scarva Road Industrial Estate
- Banbridge
- County Down
- BT32 3QD
- Northern Ireland Unit 24, Scarva Road Industrial Estate, Banbridge, County Down, BT32 3QD, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- NIBLOCK, Eric George
- Prokuristen
- NIBLOCK, Brian
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.09.2007
- Gelöscht am:
- 2020-09-22
- SIC/NACE
- 25730
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Eric George Niblock
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- A-ONE CONTROL SYSEMS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-10-31
- Letzte Einreichung: 2019-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-09-21
- Letzte Einreichung: 2019-09-07
-
A-ONE CONTROL SYSTEMS LIMITED Firmenbeschreibung
- A-ONE CONTROL SYSTEMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI066242. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.09.2007 registriert. A-ONE CONTROL SYSTEMS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen A-ONE CONTROL SYSEMS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25730" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Unit 24 erreicht werden.
Jetzt sichern A-ONE CONTROL SYSTEMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: A-One Control Systems Limited - Unit 24, Scarva Road Industrial Estate, Banbridge, County Down, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu A-ONE CONTROL SYSTEMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-09-22) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-02-07) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-02-18) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-09-04) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-10-22) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-22) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-10-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-07-16) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-07-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-10-30) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-31) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-10-30) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-07) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-08-01) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-09-10) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-08-13) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-12-09) - AR01
-
legacy (2009-07-23) - AC(NI)
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-12) - 295(NI)
-
legacy (2008-10-24) - 371S(NI)
-
legacy (2008-05-07) - 233(NI)
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-14) - 296(NI)
-
incorporation-company (2007-09-07) - NEWINC
-
legacy (2007-10-01) - 296(NI)