-
KILLULTAGH PROJECTS LIMITED - 2nd Floor, The Linenhall, 32 - 38 Linenhall Street, Belfast, Antrim, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI062391
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor, The Linenhall
- 32 - 38 Linenhall Street
- Belfast
- Antrim
- BT2 8BG
- United Kingdom 2nd Floor, The Linenhall, 32 - 38 Linenhall Street, Belfast, Antrim, BT2 8BG, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BOYD, Brendan Peter Edward
- BOYD, Frank Edward
- Prokuristen
- LAMONT, Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.12.2006
- Alter der Firma 2006-12-20 17 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Frank Boyd
- Killultagh Holdings Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- EAGLEMOUNT PROPERTIES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-15
- Letzte Einreichung: 2020-12-01
-
KILLULTAGH PROJECTS LIMITED Firmenbeschreibung
- KILLULTAGH PROJECTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI062391. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.12.2006 registriert. KILLULTAGH PROJECTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen EAGLEMOUNT PROPERTIES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor, The Linenhall erreicht werden.
Jetzt sichern KILLULTAGH PROJECTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Killultagh Projects Limited - 2nd Floor, The Linenhall, 32 - 38 Linenhall Street, Belfast, Antrim, Grossbritannien
- 2006-12-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KILLULTAGH PROJECTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-20) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-01-20) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-20) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-20) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-12-20) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-09-26) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-07) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-15) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-15) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-09-15) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-15) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-09-15) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-21) - CS01
-
resolution (2016-09-22) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-23) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2010-02-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-01-21) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-01-21) - CH03
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-05-29) - 296(NI)
-
legacy (2009-07-03) - 296(NI)
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-22) - AC(NI)
-
legacy (2008-10-21) - 98-2(NI)
-
legacy (2008-01-23) - 371S(NI)
-
legacy (2008-12-22) - 371S(NI)
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-11-23) - 233(NI)
-
particulars-of-a-mortgage-charge (2007-03-07) - 402(NI)
-
legacy (2007-01-29) - 296(NI)
-
legacy (2007-01-29) - 295(NI)
-
incorporation-company (2007-01-09) - NEWINC