-
KEEL CONTRACTORS LIMITED - 1st Floor, 34 B-D Main Street, Moira, Co. Armagh, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI050345
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st Floor
- 34 B-D Main Street
- Moira
- Co. Armagh
- BT67 0LE 1st Floor, 34 B-D Main Street, Moira, Co. Armagh, BT67 0LE UK
Management
- Geschäftsführung
- BURROWS, William Michael
- FURNEY, John George
- MCLARNON, Colm Gerard
- Prokuristen
- BURROWS, William Michael
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.04.2004
- Alter der Firma 2004-04-23 20 Jahre
- SIC/NACE
- 41201
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Colm Gerard Mclarnon
- Mr William Michael Burrows
- Mr John George Furney
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2014-04-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-07
- Letzte Einreichung: 2020-04-23
-
KEEL CONTRACTORS LIMITED Firmenbeschreibung
- KEEL CONTRACTORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI050345. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.04.2004 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41201" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2018 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.04.2014.Die Firma kann schriftlich über 1St Floor erreicht werden.
Jetzt sichern KEEL CONTRACTORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Keel Contractors Limited - 1st Floor, 34 B-D Main Street, Moira, Co. Armagh, Grossbritannien
- 2004-04-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KEEL CONTRACTORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-17) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-18) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-08-20) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-08-20) - PSC01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-01) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-29) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-01) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-04-30) - AD01
-
legacy (2013-02-01) - MG01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-05) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-04-12) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-12) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2010-05-02) - AA01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-10) - 371S(NI)
-
legacy (2009-03-01) - 233(NI)
-
legacy (2009-02-23) - 295(NI)
-
legacy (2009-02-21) - AC(NI)
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-06-06) - 371S(NI)
-
legacy (2008-03-11) - AC(NI)
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-05-15) - 371S(NI)
keyboard_arrow_right 2006
-
particulars-of-a-mortgage-charge (2006-09-11) - 402(NI)
-
legacy (2006-08-24) - AC(NI)
-
legacy (2006-07-24) - 371S(NI)
-
legacy (2006-01-08) - 295(NI)
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-06-22) - 371S(NI)
-
legacy (2005-07-03) - AC(NI)
-
legacy (2005-11-24) - 296(NI)
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-07-30) - G98-2(NI)
-
legacy (2004-07-30) - 296(NI)
-
legacy (2004-07-28) - 296(NI)
-
legacy (2004-06-24) - 295(NI)
-
resolution (2004-06-24) - RESOLUTIONS
-
legacy (2004-06-24) - UDM+A(NI)
-
legacy (2004-06-18) - 296(NI)
-
legacy (2004-04-23) - MEM(NI)
-
legacy (2004-04-23) - ARTS(NI)
-
legacy (2004-04-23) - G23(NI)
-
legacy (2004-04-23) - G21(NI)