-
PRIMROSE TOPCO LIMITED - Rosemont House Yorkdale Industrial Park, Braithwaite Street, Leeds, LS11 9XE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 12579703
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Rosemont House Yorkdale Industrial Park
- Braithwaite Street
- Leeds
- LS11 9XE
- England Rosemont House Yorkdale Industrial Park, Braithwaite Street, Leeds, LS11 9XE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOWARD, Russell Peter
- LONG, Ben
- TUCKER, Michael Andrew
- BUSBY, Timothy Mark
- TAYLOR, Howard Langton
- CRAIG, Olivia Jane Beatrice
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.04.2020
- Alter der Firma 2020-04-30 4 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-13
- Letzte Einreichung: 2023-04-29
-
PRIMROSE TOPCO LIMITED Firmenbeschreibung
- PRIMROSE TOPCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 12579703. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.04.2020 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Rosemont House Yorkdale Industrial Park erreicht werden.
Jetzt sichern PRIMROSE TOPCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Primrose Topco Limited - Rosemont House Yorkdale Industrial Park, Braithwaite Street, Leeds, LS11 9XE, Grossbritannien
- 2020-04-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRIMROSE TOPCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-02-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-02-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2023
-
capital-allotment-shares (2023-07-31) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-05-04) - CS01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2023-04-20) - SH10
-
memorandum-articles (2023-04-08) - MA
-
resolution (2023-04-08) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2023-01-05) - MA
-
resolution (2023-01-05) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-05-10) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
capital-allotment-shares (2022-12-22) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-07-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-04) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-25) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-01) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-01) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-06-16) - AA
-
resolution (2021-06-25) - RESOLUTIONS
-
second-filing-capital-allotment-shares (2021-11-25) - RP04SH01
-
resolution (2021-11-08) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2021-10-29) - SH01
-
resolution (2021-08-10) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2021-06-15) - SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-23) - AP01
-
incorporation-company (2020-04-30) - NEWINC
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-07-10) - SH08
-
capital-allotment-shares (2020-07-10) - SH01
-
memorandum-articles (2020-07-09) - MA
-
resolution (2020-07-10) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-14) - TM01
-
resolution (2020-10-20) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2020-10-08) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-07-10) - SH02
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2020-06-23) - AA01