-
RI MDC UK133 LIMITED - 8 Sackville Street, London, W1S 3DG, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 11985596
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 Sackville Street
- London
- W1S 3DG
- England 8 Sackville Street, London, W1S 3DG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CHIVERS, Michael Edward
- EMLY, Joseph Edward
- NOGUERA, Eduardo
- WITT, Jonathan Stafford
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.05.2019
- Alter der Firma 2019-05-08 5 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Realty Income Corporation
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- NEWRIVER RETAIL (NAPIER) LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 21380012P7L7I7MY2T46
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-21
- Letzte Einreichung: 2023-05-07
-
RI MDC UK133 LIMITED Firmenbeschreibung
- RI MDC UK133 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 11985596. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.05.2019 registriert. RI MDC UK133 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen NEWRIVER RETAIL (NAPIER) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 8 Sackville Street erreicht werden.
Jetzt sichern RI MDC UK133 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ri Mdc Uk133 Limited - 8 Sackville Street, London, W1S 3DG, England, Grossbritannien
- 2019-05-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RI MDC UK133 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-07-12) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-03-03) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-04-04) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-07-11) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-07-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-07-11) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-07-11) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-07-11) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-07-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-05-10) - CS01
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2023-05-10) - MR05
-
resolution (2023-09-01) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2023-09-01) - MA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-07-12) - PSC02
-
certificate-change-of-name-company (2023-07-12) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2022
-
legacy (2022-06-21) - CAP-SS
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-08-03) - AA
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2022-06-21) - SH19
-
legacy (2022-06-21) - SH20
-
resolution (2022-06-21) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-07-08) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-02-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-02-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-12-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-10-27) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-03-17) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-04-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-12) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-10-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-11) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-06-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-01) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-05-01) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
incorporation-company (2019-05-08) - NEWINC
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-04) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-03) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2019-08-12) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-12) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-03) - PSC05
-
resolution (2019-07-03) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-07-03) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-06-27) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-06-26) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-14) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-07-02) - SH08