-
SC TOPCO LIMITED - The Forge, Church Street West, Woking, GU21 6HT, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 11532813
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Forge
- Church Street West
- Woking
- GU21 6HT
- England The Forge, Church Street West, Woking, GU21 6HT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- JERVIS, Ryan David
- TORRINGTON, Trevor Michael
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.08.2018
- Alter der Firma 2018-08-23 5 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Aspris Children's Services Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- AGHOCO 1760 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-05-31
- Letzte Einreichung: 2023-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-26
- Letzte Einreichung: 2023-08-12
-
SC TOPCO LIMITED Firmenbeschreibung
- SC TOPCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 11532813. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.08.2018 registriert. SC TOPCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen AGHOCO 1760 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über The Forge erreicht werden.
Jetzt sichern SC TOPCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sc Topco Limited - The Forge, Church Street West, Woking, GU21 6HT, Grossbritannien
- 2018-08-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SC TOPCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
legacy (2024-05-28) - AGREEMENT2
-
legacy (2024-05-28) - GUARANTEE2
-
legacy (2024-05-28) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2024-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-07-04) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-02-23) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2023-06-09) - AA
-
legacy (2023-06-09) - GUARANTEE2
-
legacy (2023-06-09) - PARENT_ACC
-
legacy (2023-06-09) - AGREEMENT2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-08-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-05-23) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-02-28) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-02-09) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2022-02-09) - PSC09
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-02-04) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-02-04) - TM01
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2022-01-31) - RP04CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-02-04) - MR04
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2022-01-25) - RP04CS01
-
capital-allotment-shares (2022-01-24) - SH01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-30) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-05-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-04-24) - AA
-
legacy (2020-01-15) - CAP-SS
-
resolution (2020-01-15) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-01-11) - MR04
-
confirmation-statement (2020-09-03) - CS01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-02-11) - SH19
-
memorandum-articles (2020-02-26) - MA
keyboard_arrow_right 2019
-
second-filing-capital-allotment-shares (2019-03-29) - RP04SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-24) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-03) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-08-22) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-07-26) - PSC08
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-26) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-21) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2019-03-30) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-01) - MR01
-
resolution (2019-02-27) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-10) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-01-08) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2019-01-23) - SH02
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-28) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-28) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-28) - MR01
-
capital-allotment-shares (2018-12-21) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-21) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-28) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-28) - PSC07
-
incorporation-company (2018-08-23) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-28) - TM01