-
FORTUNE BRANDS GLOBAL PLUMBING GROUP II UK CO. LIMITED - Fortune Brands Innovations Building, 2 Pioneer Way, Wolverhampton, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 11002276
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Fortune Brands Innovations Building
- 2 Pioneer Way
- Wolverhampton
- West Midlands
- WV9 5FH
- England Fortune Brands Innovations Building, 2 Pioneer Way, Wolverhampton, West Midlands, WV9 5FH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- JOHN-FEATHERBY, Esyllt
- PLATT, James David
- TETER, Todd Richard
- Prokuristen
- PLA, Angela Marie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.10.2017
- Alter der Firma 2017-10-09 6 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Fortune Brands Global Plumbing Group I Uk Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-15
- Letzte Einreichung: 2023-11-01
-
FORTUNE BRANDS GLOBAL PLUMBING GROUP II UK CO. LIMITED Firmenbeschreibung
- FORTUNE BRANDS GLOBAL PLUMBING GROUP II UK CO. LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 11002276. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.10.2017 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Fortune Brands Innovations Building erreicht werden.
Jetzt sichern FORTUNE BRANDS GLOBAL PLUMBING GROUP II UK CO. LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fortune Brands Global Plumbing Group Ii Uk Co. Limited - Fortune Brands Innovations Building, 2 Pioneer Way, Wolverhampton, West Midlands, Grossbritannien
- 2017-10-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FORTUNE BRANDS GLOBAL PLUMBING GROUP II UK CO. LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-05-09) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-04-22) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-03-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-01-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-01-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-12-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-01-18) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-12-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-12-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
gazette-notice-compulsory (2022-03-08) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-12-19) - CS01
-
capital-allotment-shares (2022-11-18) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-04-19) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-03-19) - DISS40
keyboard_arrow_right 2021
-
gazette-notice-compulsory (2021-09-14) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-11-01) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-01) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-11-01) - AP01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-10-01) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
auditors-resignation-company (2020-01-07) - AUD
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-28) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-13) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-09-10) - GAZ1
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-19) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-11-07) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-07) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-11-07) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-11-26) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-23) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-12-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
incorporation-company (2017-10-09) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2017-11-02) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-16) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-16) - PSC07