-
MAUVEWORX LTD - 1 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10989151
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Nimrod Way
- Wimborne
- Dorset
- BH21 7SH
- England 1 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FITZ-GERALD, Nicholas John Purcell
- MARTIN, James Rowland
- MARTIN, Tobias Giles
- PARKER, Roy
- Prokuristen
- FITZ-GERALD, Nicholas John Purcell
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 29.09.2017
- Alter der Firma 2017-09-29 6 Jahre
- SIC/NACE
- 17290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Sps Martin Holdings Ltd
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- SPECIALIST PRINT SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-17
- Letzte Einreichung: 2022-11-03
-
MAUVEWORX LTD Firmenbeschreibung
- MAUVEWORX LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10989151. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.09.2017 registriert. MAUVEWORX LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SPECIALIST PRINT SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "17290" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 Nimrod Way erreicht werden.
Jetzt sichern MAUVEWORX LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mauveworx Ltd - 1 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH, Grossbritannien
- 2017-09-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MAUVEWORX LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-10-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-09) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-10) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-10) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-08-05) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-11-26) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-20) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-10-03) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-04-01) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-01-02) - SH01
-
change-of-name-notice (2018-04-03) - CONNOT
-
resolution (2018-04-03) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-11) - TM01
-
capital-allotment-shares (2018-10-05) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-06-11) - AA01
-
capital-name-of-class-of-shares (2018-01-02) - SH08
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-05) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-05) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-06-11) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-05) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-12-28) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-17) - MR01
-
incorporation-company (2017-09-29) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-30) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-30) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-21) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-30) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-31) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-31) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-03) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-11-03) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-03) - CS01
-
resolution (2017-11-03) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-10-30) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-16) - MR01