-
AH OLD TRAFFORD LIMITED - Hilton House, 26 - 28 Hilton Street, Manchester, M1 2EH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10984975
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hilton House
- 26 - 28 Hilton Street
- Manchester
- M1 2EH
- England Hilton House, 26 - 28 Hilton Street, Manchester, M1 2EH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LORD, Howard Barry Philip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.09.2017
- Alter der Firma 2017-09-27 6 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Cert Property Group Limited
- Ms Daphne Zhen Wee
- Mr Denka Zhenke Wee
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active — Active proposal to strike off
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-05-31
- Letzte Einreichung: 2023-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-22
- Letzte Einreichung: 2023-07-08
-
AH OLD TRAFFORD LIMITED Firmenbeschreibung
- AH OLD TRAFFORD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10984975. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.09.2017 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hilton House erreicht werden.
Jetzt sichern AH OLD TRAFFORD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ah Old Trafford Limited - Hilton House, 26 - 28 Hilton Street, Manchester, M1 2EH, Grossbritannien
- 2017-09-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AH OLD TRAFFORD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-01-30) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2024-02-22) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2024-03-05) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-07-26) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-09-13) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-07-13) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-25) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-09-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-01) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-24) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-02-24) - PSC02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-08) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-08) - CH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-06-21) - AA01
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-23) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-05-07) - AD01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-12-04) - DISS16(SOAS)
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-09-13) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-21) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-12-22) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-09-25) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-09) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-06-26) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-01-21) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-02-28) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-03-19) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-06) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-08-06) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-06) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-06-20) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-12-10) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-09) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-01) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-01) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-01) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-09) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-12) - CS01
-
capital-allotment-shares (2018-03-29) - SH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-02) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-21) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-11-09) - PSC05
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-27) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-27) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
incorporation-company (2017-09-27) - NEWINC